CARLOS GOMEZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CARLOS GOMEZ SL
CIF B80151749
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Página Web www.centrimerca.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARLOS GOMEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARLOS GOMEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmona Repolle Antonio | Apoderado Mancomunado | 24/02/2015 | 29/06/2023 |
Carrasco Sanchez Jose Ignacio | Consejero | 12/06/2017 | 29/06/2023 |
Gomez Garcia Maria Del Carmen | Apoderado | 29/06/2023 | |
Lopez Tello Garcia Gloria | Apoderado | 29/06/2023 | |
Paradela Portillo Raquel | Apoderado Mancomunado | 24/02/2015 | 29/06/2023 |
Paradela Portillo Raquel | Presidente | 12/06/2017 | 29/06/2023 |
Paradela Portillo Raquel | Consejero Delegado | 12/06/2017 | 29/06/2023 |
Paradela Portillo Raquel | Consejero | 12/06/2017 | 29/06/2023 |
Sanz Sanchez Fernando | Consejero | 12/06/2017 | 29/06/2023 |
Sanz Sanchez Fernando | Secretario | 12/06/2017 | 29/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARLOS GOMEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 63, S 8, H M 31093, I/A 17 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 63, S 8, H M 31093, I/A 17 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 63, S 8, H M 31093, I/A 17 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 63, S 8, H M 31093, I/A 17 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 63, S 8, H M 31093, I/A 16 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 61, S 8, H M 31093, I/A 15 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 61, S 8, H M 31093, I/A 15 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
- Otras modificaciones estatutarias: de los estatutos. Nueva redaccion del articulo 20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 61, S 8, H M 31093, I/A 14 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 224, S 8, H M 31093, I/A 13 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 20 y 21 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 222, S 8, H M 31093, I/A 12 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28