VEREDA DEL VALLE SA
Dirección social Calle Ramon y Cajal, 112
Código Postal 45512
Municipio Portillo de Toledo
Provincia Toledo
Razón Social VEREDA DEL VALLE SA
CIF A45609609
Capital Social 6600800.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 18/11/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lopez Gomez Fructuoso
ORGANIGRAMA DE VEREDA DEL VALLE SA
VINCULACIONES DE VEREDA DEL VALLE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VEREDA DEL VALLE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAF PROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL | Secretario | 03/01/2019 | |
JAF PROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL | Consejero Delegado Solidario | 03/01/2019 | |
JAF PROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL | Consejero | 03/01/2019 | |
Lopez Gomez Fructuoso | Consejero Delegado Solidario | 03/01/2019 | |
Lopez Gomez Fructuoso | Presidente | 03/01/2019 | |
Lopez Gomez Fructuoso | Consejero | 03/01/2019 | |
Lopez Gonzalez Alberto | Consejero Delegado Solidario | 03/01/2019 | |
Lopez Gonzalez Alberto | Consejero | 03/01/2019 | |
Lopez Gonzalez Jose Manuel | Consejero Delegado Solidario | 03/01/2019 | |
Lopez Gonzalez Jose Manuel | Consejero | 03/01/2019 |
ACTOS BORME DE VEREDA DEL VALLE SA
Capital Anterior: | 8.000.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.399.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.600.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 24, S 8, H TO 24786, I/A 15 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-45
- Desembolsado: 10.336,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 24, S 8, H TO 24786, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-45
- Rectificada la cantidad desembolsada siendo la correcta 104.413 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 24, S 8, H TO 24786, I/A 13 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-45
- Cambiado el representante persona fisica de "DIVERSIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL" por doña Emma Antolín Granet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 36, S 8, H TO 24786, I/A 12 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-45
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 36, S 8, H TO 24786, I/A 12 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-45
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 36, S 8, H TO 24786, I/A 12 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-45
- Cambiado el representante persona física en la Sociedad "PROMOTORA GE-TRES, SA", siendo el actual Don Miguel Angel Arranz Alonso de Celada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 36, S 8, H TO 24786, I/A 11 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-45
- Desembolsado: 104.450,94 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 36, S 8, H TO 24786, I/A 10 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-45
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 35, S 8, H TO 24786, I/A 9 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-45
- Desembolsado: 486.051,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 35, S 8, H TO 24786, I/A 8 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-45