VENTA LA NEGRA SL
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Razón Social VENTA LA NEGRA SL
CIF B41037748
Actividad Cultivo de arroz
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rizo Hurtado De Mendoza Encarnacion
ORGANIGRAMA DE VENTA LA NEGRA SL
VINCULACIONES DE VENTA LA NEGRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VENTA LA NEGRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peralta Revuelta Rafael Angel | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/04/2018 | |
Rizo Hurtado De Mendoza Encarnacion | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/04/2018 | |
Rizo Hurtado De Mendoza Encarnacion | Presidente | 30/04/2018 | |
Rizo Hurtado De Mendoza Encarnacion | Consejero | 30/04/2018 | |
Peralta Rizo Carlos | Consejero | 07/07/2016 | |
Peralta Pineda Rafael | Consejero | 16/05/2013 | |
Peralta Revuelta Rafael Angel | Secretario | 16/05/2013 | |
Peralta Revuelta Rafael Angel | Consejero | 16/05/2013 | |
Rizo Hurtado Maria Encarnacion | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 16/05/2013 | |
Rizo Hurtado Maria Encarnacion | Consejero | 16/05/2013 |
ACTOS BORME DE VENTA LA NEGRA SL
- AMPLIADO EL LIMITE DE LA FACULTAD NUMERO 3) CONCEDIDA A LOS CONSEJEROS DELEGADOS SOLIDARIOS DON RAFAEL ANGEL PERALTA REVUELTA Y DOÑA MARIA ENCARNACION RIZO HURTADO DE MENDOZA HASTA UN MAXIMO DE 30.000 EUROS POR OPERACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 24, S 8, H SE 10113, I/A 12 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-41
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 19, S 8, H SE 10113, I/A 11 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-41
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 19, S 8, H SE 10113, I/A 11 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-41
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 19, S 8, H SE 10113, I/A 11 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 17, S 8, H SE 10113, I/A 10 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 17, S 8, H SE 10113, I/A 10 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-41
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 17, S 8, H SE 10113, I/A 10 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-41
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 17, S 8, H SE 10113, I/A 10 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 18º- Duración de cargo de administración y retribución.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 17, S 8, H SE 10113, I/A 9 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 15, S 8, H SE 10113, I/A 8 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-41