RECAMBIOS Y SERVICIOS V TRUCK SL
Dirección social Avda de Milan, 18
Código Postal 19200
Municipio Azuqueca de Henares
Provincia Guadalajara
Mapa Ver Mapa
Razón Social RECAMBIOS Y SERVICIOS V TRUCK SL
CIF B87334819
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 23/07/2015
Teléfono 91 629 75 52
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Natho Gamboa Alejandro
Propietario IMPLEMENTOS DEL RECAMBIO SL
ORGANIGRAMA DE RECAMBIOS Y SERVICIOS V TRUCK SL
VINCULACIONES DE RECAMBIOS Y SERVICIOS V TRUCK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECAMBIOS Y SERVICIOS V TRUCK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Carrillo Sebastian Ignacio | Apoderado | 23/01/2025 | |
Novion Rivera Macarena | Apoderado | 23/01/2025 | |
Rubio Zapata Fernando Cristian | Apoderado Mancomunado | 26/09/2024 | |
Rubio Zapata Fernando Cristian | Apoderado Solidario | 26/09/2024 | |
Novion Verdugo Andres | Consejero | 31/10/2022 | |
Adriazola Granifo Felipe Andres | Apoderado | 29/06/2022 | |
Adriazola Granifo Felipe Andres | Apoderado Mancomunado | 19/05/2022 | |
Castro Escobar Matias | Apoderado Mancomunado | 19/05/2022 | |
IMPLEMENTOS DEL RECAMBIO SL | Socio Unico | 19/05/2022 | |
Moragrega Diaz Joaquin Juan | Apoderado Mancomunado | 19/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECAMBIOS Y SERVICIOS V TRUCK SL
- AVDA MILAN, 18 A-2-POLIGONO AIDA 19200 (AZUQUECA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GU 12879, I/A 2 (04/03/2025)
CVE: BORME-A-2025-51-19
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 608004, I/A 9 (23/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-20-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 608004, I/A 9 (23/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-20-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 608004, I/A 8 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
- C/ ATALAYA, NUMERO 6, POLIGONO INDUSTRIAL EL ALAMO (FUENLABRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33782 , F 106, S 8, H M 608004, I/A 7 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33782 , F 106, S 8, H M 608004, I/A 7 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33782 , F 106, S 8, H M 608004, I/A 7 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33782 , F 104, S 8, H M 608004, I/A 6 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33782 , F 103, S 8, H M 608004, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Apoderado Mancomunado
- Adriazola Granifo Felipe Andres
- Amenabar Larrain Juan Cristobal
- Castro Escobar Matias
- Moragrega Diaz Joaquin Juan
- Natho Gamboa Alejandro
- Novion Verdugo Andres
- Novion Verdugo German Alfredo
- Novion Verdugo Juan-francisco
- Peñafiel Gandulia German Eduardo
- Riquelme Gonzalez Pablo Christian
- Verdugo Bosch Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33782 , F 102, S 8, H M 608004, I/A 4 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28