FINCA LA CICUTA SL
Dirección social Calle Ingeniero La Cierva, 3
Código Postal 41960
Municipio Gines
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social FINCA LA CICUTA SL
CIF B90240748
Capital Social 3559400.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/01/2016
Teléfono 95 531 47 92
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Murube Gallego Asuncion
ORGANIGRAMA DE FINCA LA CICUTA SL
VINCULACIONES DE FINCA LA CICUTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCA LA CICUTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual-terrats Murube Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2019 | |
Pascual-terrats Murube Maria Asuncion | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2019 | |
Murube Gallego Asuncion | Presidente | 16/02/2018 | |
Murube Gallego Asuncion | Consejero | 10/02/2016 | |
Pascual-terrats Murube Jose Luis | Consejero | 10/02/2016 | |
Pascual-terrats Murube Maria Asuncion | Secretario | 10/02/2016 | |
Pascual-terrats Murube Maria Asuncion | Consejero | 10/02/2016 |
ACTOS BORME DE FINCA LA CICUTA SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 109, S 8, H SE108289, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-41
Capital Anterior: | 3.467.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 92.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.559.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 109, S 8, H SE108289, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 108, S 8, H SE108289, I/A 5 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-41
Capital Anterior: | 2.904.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 563.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.467.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 108, S 8, H SE108289, I/A 5 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-41
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 107, S 8, H SE108289, I/A 4 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-41
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 107, S 8, H SE108289, I/A 4 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-41
- Otras modificaciones estatutarias: 26 bis. Prohibición de competencia. 27. Retribución
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 106, S 8, H SE108289, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-41
- Determina el número de consejeros en TRES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 106, S 8, H SE108289, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 106, S 8, H SE108289, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 106, S 8, H SE108289, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-41