COMAPA CENTRE SL - EXTINGUIDA
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social COMAPA CENTRE SL
CIF B63592620
Capital Social 4400000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/07/2004
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente ALPINA FORMIGAL SL
VINCULACIONES DE COMAPA CENTRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMAPA CENTRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPINA FORMIGAL SL | Presidente | 21/08/2014 | 24/11/2014 |
ALPINA FORMIGAL SL | Consejero | 21/08/2014 | 24/11/2014 |
ARGOS DEU SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/08/2014 | 24/11/2014 |
ARGOS DEU SL | Consejero | 21/08/2014 | 24/11/2014 |
Cartagena Vime Roger | REPR.143 RRM | 18/02/2013 | 24/11/2014 |
DISRAY TRADE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/08/2014 | 24/11/2014 |
DISRAY TRADE SL | Consejero | 21/08/2014 | 24/11/2014 |
GESCAT LLEVANT SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/08/2014 | 24/11/2014 |
GESCAT LLEVANT SL | Secretario | 25/02/2011 | 24/11/2014 |
GESCAT LLEVANT SL | Consejero | 25/02/2011 | 24/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMAPA CENTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44418 , F 73, S 8, H B 290042, I/A 14 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 632/2014, AUTO FIRME DE FECHA 24/10/2014, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44418 , F 73, S 8, H B 290042, I/A 14 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 632/2014, AUTO FIRME DE FECHA 22/07/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44418 , F 72, S 8, H B 290042, I/A 13 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44418 , F 72, S 8, H B 290042, I/A 13 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.15,16,19,22. COMPOSICION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,DURACION DEL CARGO DE CONSEJERO,MAYORIAS NECESARIAS PARA LA ADOPCION DE ACUERDOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36877 , F 201, S 8, H B 290042, I/A 12 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36877 , F 201, S 8, H B 290042, I/A 12 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36877 , F 201, S 8, H B 290042, I/A 12 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36877 , F 201, S 8, H B 290042, I/A 11 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36877 , F 201, S 8, H B 290042, I/A 11 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36877 , F 200, S 8, H B 290042, I/A 10 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-08